logo City Hall
1 Dr. Carlton B. Goodlett 
Place 
San Francisco, CA  94102-
4689
City and County of San Francisco Legislation Details File #:  Version: 2 240672 Name: Section 559 Reimbursable Services Agreement - 
Retroactive - United States Customs and Border 
Protection at San Francisco International Airport
Status: Type: Resolution Passed File created: In control: 6/18/2024 Clerk of the Board On agenda: Final action: 6/18/2024 8/1/2024 Enactment date: 8/1/2024 417-24 Enactment #: Title: Resolution retroactively approving the Section 559 Reimbursable Services Agreement, Contract No.  50020, between United States Customs and Border Protection and the City and County of San  Francisco, acting by and through its Airport Commission, with a commencement date of November  25, 2014, for an indefinite term, terminable upon either party by 90 days’ written notice. Sponsors: Attachments: 1. Leg Ver1, 2. Original Agmt 111414, 3. Air Comm Reso No. 14-0167 and Memo 081914, 4. Air 
Comm Reso No. 19-0146 and Memo 060419, 5. Air Comm Reso No. 24-0126 060424, 6. Air Comm 
Memo 060424, 7. AIR Ltr 060624, 8. BLA Rpt 071724, 9. Cmte Pkt 071724, 10. Leg Ver2, 11. Board 
Pkt 072324, 12. AIR Stmnt on Retro 072224, 13. Leg Final, 14. Executed Original Agmt 090924
Action By Date Action Result Ver. RECEIVED FROM DEPARTMENT Clerk of the Board 6/7/2024 1 RECEIVED AND ASSIGNED President 6/18/2024 1 AMENDED, AN AMENDMENT OF THE 
WHOLE BEARING NEW TITLE
Budget and Finance Committee 7/17/2024 1 Pass RECOMMENDED AS AMENDED Budget and Finance Committee 7/17/2024 2 Pass Board of Supervisors 7/23/2024 2 APPROVED Mayor 8/1/2024 2 RECEIVED FROM DEPARTMENT Clerk of the Board 9/9/2024 2