logo City Hall
1 Dr. Carlton B. Goodlett 
Place 
San Francisco, CA  94102-
4689
City and County of San Francisco Legislation Details File #:  Version: 1 150258 Name: Petitions and Communications Status: Type: Communication Filed File created: In control: 3/16/2015 Clerk of the Board On agenda: Final action: 3/24/2015 Enactment date: Enactment #: Title: Petitions and Communications received from March 9, 2015, through March 16, 2015, for reference  by the President to Committee considering related matters, or to be ordered filed by the Clerk on  March 24, 2015. Personal information that is provided in communications to the Board of Supervisors is subject to  disclosure under the California Public Records Act and the San Francisco Sunshine Ordinance.   Personal information will not be redacted. From concerned citizens, regarding teaching Catholic doctrine.  2 letters.  Copy: Each Supervisor.  (1) From City Administrator, regarding City Hall Centennial Preservation Fund report.  Copy: Each  Supervisor.  File No. 150051.  (2) From Public Works, notice of commencement of emergency work on Telegraph Hill Rock Slope  Improvement Project.  Copy: Each Supervisor.  (3) From William Tickle, regarding regulation of transportation network companies.  (4) From concerned citizens, regarding proposed emergency interim zoning controls.  File No. 150192.  5  letters.  Copy: Each Supervisor.  (5) From Public Health, regarding grant budget revision for Racial and Ethnic Approaches to Community  Health - Heart Healthy SF.  Copy: Each Supervisor.  (6) From Product Stewardship Institute Inc., regarding support for Safe Drug Disposal Stewardship  Ordinance.  File No. 141095.  Copy: Each Supervisor.  (7) From Aaron Goodman, regarding Housing Element.  File No. 150155.  (8) From Fish and Game, regarding Notice of Findings on flat-tailed horned lizard.  Copy: Each  Supervisor.  (9) From Sandy Weil, regarding Stow Lake Boathouse lease.  Copy: Each Supervisor.  (10) From Planning, regarding Article 10 Landmark Designation of 2168-2174 Market Street, the Swedish  American Hall.  (11) From Public Works, regarding 2013-2014 annual report.  Copy: Each Supervisor.  (12) From Mayor Lee, regarding reappointment to the Municipal Transportation Agency Board of Directors:     Joel Ramos - term ending March 1, 2019.  (13) From Public Works, regarding justification for 12B waiver for Ventura County contract.  Copy: Each  Supervisor.  (14) From Controller, regarding Andre-Boudin Bakeries, Inc. performance audit report from January 1,  2012, through December 31, 2013.  (15) From Controller, regarding five-year financial plan FYs 2016-2020 update.  (16)
Sponsors: Attachments: 1. Board Pkt 032415
Action By Date Action Result Ver.