logo City Hall
1 Dr. Carlton B. Goodlett 
Place 
San Francisco, CA  94102-
4689
City and County of San Francisco Legislation Details File #:  Version: 1 150344 Name: Petitions and Communications Status: Type: Communication Filed File created: In control: 4/6/2015 Clerk of the Board On agenda: Final action: 4/14/2015 Enactment date: Enactment #: Title: Petitions and Communications received from March 30, 2015, through April 6, 2015, for reference by  the President to Committee considering related matters, or to be ordered filed by the Clerk on April 14,  2015. Personal information that is provided in communications to the Board of Supervisors is subject to  disclosure under the California Public Records Act and the San Francisco Sunshine Ordinance.   Personal information will not be redacted. From Public Works, submitting Notice of Commencement of Emergency Work.  Copy: Each  Supervisor.  (1) From United Farm Workers, regarding Gerawan farm workers represented by the United Farm  Workers.  File No. 150126.  (2) From various organizations, regarding San Francisco Watershed.  2 letters.  File No. 150165.  Copy:  Each Supervisor.  (3) From Maxence Nachury, regarding San Francisco Watershed.  Copy: Each Supervisor.  (4) From concerned citizens, regarding transportation network companies.  2 letters.  Copy: Each  Supervisor.  (5) From Sutton Place Management, LLC, submitting notice of mass layoff.  Copy: Each Supervisor.  (6) From Office of Economic and Workforce Development, submitting FY2014-2015 Annual Report on  Local Hiring Policy for Construction.  Copy: Each Supervisor.  (7) From Entertainment Commission, submitting Extended Hours Premises quarterly report from January  1 through March 31, 2015.  Copy: Each Supervisor.  (8) From Carol Walker, regarding San Francisco Municipal Pier.  Copy: Each Supervisor.  (9) From Charles Byrd, regarding police body camera program.  Copy: Each Supervisor.  (10) From Mayor Lee, regarding appointment to the Commission on the Status of Women:  (11)    Debbie Mesloh - term ending November 18, 2018 From Clerk of the Board, reporting that the following individuals have submitted Form 700 Statements  as of March 31, 2015:  (12)    Lauterborn, Peter George - Legislative Aide - Annual    Goosen, Carolyn Ji Jong - Legislative Aide - Annual    Cretan, Jeffrey Vahan - Legislative Aide - Annual    Scanlon, Olivia Siobhan - Legislative Aide - Annual    Fried, Jason - LAFCo - Annual    Low, Jennifer - Legislative Aide - Annual    Chan, Yoyo - Legislative Aide - Annual    Tugbenyoh, Mawuli Kofi-Doe - Legislative Aide - Annual    Taylor, Adam Carvey - Legislative Aide - Annual    Louie, Arthur - Budget Analyst
   Young, Victor - Administrator, Sunshine Ordinance Task Force From Hanson Bridgett, LLP, regarding 53 States Street categorical exemption appeal.  File No.  150167.  2 letters.  Copy: Each Supervisor.  (13) From Clerk of the Board, regarding report on surplus city property.  (14) From Supervisor Norman Yee, regarding absence from the Board of Supervisor meeting.  (15) From Sunshine Ordinance Task Force, regarding membership and attendance.  Copy: Each  Supervisor.  (16) From State Board of Equalization, regarding Taxpayers’ Bill of Rights annual public hearings.  Copy:  Each Supervisor.  (17) From Sheriff, regarding waiver request for Praeses, LLC.  Copy: Each Supervisor.  (18) From Controller, submitting report on the implementation statuses of its recommendations for FY2014 -2015, second quarter.  (19) From Public Health, regarding grant budget revision for AIDS prevention studies.  Copy: Each  Supervisor.  (20) From Public Health, regarding grant budget revision for Health Resources and Services  Administration Title IV Services.  Copy: Each Supervisor.  (21) From Clerk of the Board, reporting that the following individuals have submitted Form 700 Statements  as of April 6, 2015:  (22)    Lee, Ivy - Legislative Aide - Annual    Power, Andres - Legislative Aide - Annual Sponsors: Attachments: 1. Board Pkt 041415
Action By Date Action Result Ver.