logo City Hall
1 Dr. Carlton B. Goodlett 
Place 
San Francisco, CA  94102-
4689
City and County of San Francisco Legislation Details File #:  Version: 1 150386 Name: Petitions and Communications Status: Type: Communication Filed File created: In control: 4/13/2015 Board of Supervisors On agenda: Final action: 4/21/2015 Enactment date: Enactment #: Title: Petitions and Communications received from April 6, 2015, through April 13, 2015, for reference by  the President to Committee considering related matters, or to be ordered filed by the Clerk on April 21,  2015. Personal information that is provided in communications to the Board of Supervisors is subject to  disclosure under the California Public Records Act and the San Francisco Sunshine Ordinance.   Personal information will not be redacted. From Public Health, submitting report of feasible technologies for implementation of Article 38.  Copy:  Each Supervisor.  (1) From Controller, submitting report on ABC Parking revenues for Kezar Lot from February 2012  through January 2014.  Copy: Each Supervisor.  (2) From Public Utilities Commission, regarding public participation in development and implementation of  a Groundwater Sustainability Plan for the North Westside Groundwater Basin.  Copy: Each  Supervisor.  (3) From Sheriff, submitting waiver request for Rapid Notify, Inc.  Copy: Each Supervisor.  (4) From Airport, submitting waiver request for Gartner, Inc.  Copy: Each Supervisor.  (5) From Environment, regarding CleanPowerSF.  Copy: Each Supervisor.  (6) From Roland Salvato, regarding emission standards for tour buses.  Copy: Each Supervisor.  (7) From Charles Byrd, regarding police body camera program.  Copy: Each Supervisor.  (8) From Martin Reed, regarding Commission on Education.  Copy: Each Supervisor.  (9) From Treasurer and Tax Collector, submitting 2014 annual report for special school parking event  permit revenue.  Copy: Each Supervisor.  (10) From Theo Revlock, regarding project at 53 States Street.  Copy: Each Supervisor.  (11) From Protect Noe’s Charm, regarding demolition of 369 Valley Street.  Copy: Each Supervisor.  (12) From Mayor Lee, designating Supervisor Tang as Acting-Mayor from April 9 to April 12.  Copy: Each  Supervisor.  (13) From Marilyn Vassallo, regarding kidnapping of 43 students in Mexico.  Copy: Each Supervisor.  (14) From Controller, regarding Public Utilities Commission: Follow-up of 2012 Audit of the Job Order  Contract Program.  Copy: Each Supervisor.  (15) From Services & Advocacy for Gay, Lesbian, Bisexual & Transgender Elders, regarding LGBT Long- term Care Facility Residents’ Bill of Rights.  Copy: Each Supervisor.  (16) From Economic and Workforce Development, submitting quarterly dashboard for 4th quarter 2014.  
Copy: Each Supervisor.  (17) From City Administrator, regarding proposed Ten Year Capital Expenditure Plan for FYs 2016-2025.   Copy: Each Supervisor.  (18) From Clerk of the Board, reporting that the following individuals have submitted Form 700 Statements  as of April 6, 2015:  (19)    Veneracion, April - Legislative Aide - Annual    Lim, Victor - Legislative Aide - Annual From Clerk of the Board, reporting that the following individuals have submitted Form 700 Statements  as of April 10, 2015:  (20)    Power, Andres - Legislative Aide - Annual    Lee, Ivy - Legislative Aide - Annual    Allbee, Nate - Legislative Aide - Annual and Leaving office    Angulo, Sunny - Legislative Aide - Annual Sponsors: Attachments: 1. Board Pkt 042115
Action By Date Action Result Ver.