logo City Hall
1 Dr. Carlton B. Goodlett 
Place 
San Francisco, CA  94102-
4689
City and County of San Francisco Legislation Details File #:  Version: 4 150997 Name: Golden State Warriors Event Center at Mission Bay 
- Street and Easement Vacations
Status: Type: Ordinance Passed File created: In control: 10/20/2015 Clerk of the Board On agenda: Final action: 12/17/2015 Enactment date: 12/17/2015 232-15 Enactment #: Title: Ordinance ordering the summary vacation of four easements for water line, sanitary sewer, and/or  storm water purposes and two offers of dedication within portions of Assessor’s Block No. 8722, Lot  Nos. 1 and 8 within the Mission Bay South Redevelopment Plan Area for the Golden State Warriors  Event Center and Mixed-Use Development at Mission Bay South Blocks 29-32; authorizing a  termination and quitclaim of the easements and other City and County of San Francisco rights and  interest in the vacated areas; authorizing the General Manager of the Public Utilities Commission and  the Director of Property to execute the quitclaim deeds for the vacated easements and vacation area;  providing license agreement(s), including if appropriate, a retroactive extension of the previously  executed agreement, for the public’s use of the temporary Terry A. Francois Boulevard Connector  Road; adopting findings pursuant to the California Environmental Quality Act; and making findings of  consistency with the Mission Bay South Redevelopment Plan, the General Plan, and the eight priority  policies of Planning Code, Section 101.1, for the actions contemplated in this Ordinance. Sponsors: Mayor, Mark Farrell Attachments: 1. Leg Ver1, 2. Leg Ver2, 3. Leg Dig Ver2, 4. Leg Ver3, 5. Leg Dig Ver3, 6. Referral Memo 102315, 7. 
SUR Maps, 8. Easement Agreements, 9. Grant Deeds, 10. Grant of Water Main Easement, 11. 
License Agreement, 12. Offers of Dedication, 13. Quitclaim Deeds, 14. Termination of Easements, 15. 
Notice of Public Hearing 110915, 16. OCII Determination 110415, 17. PW Order No. 184229, 18. 
Comm Pkt 110915, 19. General Plan Referral 110415, 20. Easement Vacation Ltr 110915, 21. 
Planning Comm Motion No. 19502, 22. Public Correspondence, 23. Board Pkt 120815, 24. SFPUC 
Reso No. 15-0235, 25. Leg Ver4, 26. Leg Dig Ver4, 27. Board Pkt 121515, 28. Leg Final
Action By Date Action Result Ver. ASSIGNED UNDER 30 DAY RULE President 10/6/2015 1 SUBSTITUTED AND ASSIGNED President 10/20/2015 2 REFERRED TO DEPARTMENT Clerk of the Board 10/23/2015 2 NOTICED Clerk of the Board 10/25/2015 3 NOTICED Clerk of the Board 11/1/2015 3 AMENDED, AN AMENDMENT OF THE 
WHOLE BEARING NEW TITLE
Budget and Finance Committee 11/9/2015 2 Pass RECOMMENDED AS AMENDED Budget and Finance Committee 11/9/2015 3 Pass AMENDED Board of Supervisors 12/8/2015 3 Pass PASSED ON FIRST READING AS 
AMENDED
Board of Supervisors 12/8/2015 4 Pass FINALLY PASSED Board of Supervisors 12/15/2015 4 Pass APPROVED Mayor 12/17/2015 4