logo City Hall
1 Dr. Carlton B. Goodlett 
Place 
San Francisco, CA  94102-
4689
City and County of San Francisco Legislation Details File #:  Version: 1 161164 Name: Development Agreement - Sunnydale Development 
Co., LLC - Sunnydale HOPE SF Project
Status: Type: Ordinance Passed File created: In control: 10/25/2016 Clerk of the Board On agenda: Final action: 2/1/2017 Enactment date: 2/1/2017 018-17 Enactment #: Title: Ordinance approving a Development Agreement between the City and County of San Francisco, the  Housing Authority of the City and County of San Francisco, and Sunnydale Development Co., LLC, for  the Sunnydale HOPE SF Project at the approximately 50-acre site located in Visitacion Valley and  generally bounded by McLaren Park to the north, Crocker Amazon Park to the west, Hahn Street to  the east, and Velasco to the south; confirming the Development Agreement’s compliance with, or  waiving certain provisions of, Administrative Code, Chapters 14B, 29, and 56; approving the use of  impact fees and exactions for improvements and other community benefits, as set forth in the  Development Agreement, and waiving any conflicting fee provisions in Planning Code, Article 4;  ratifying past actions taken in connection with the Development Agreement; authorizing further actions  taken consistent with the Ordinance; making findings under the California Environmental Quality Act;  and making findings of conformity with the General Plan, and with the eight priority policies of  Planning Code, Section 101.1. Sponsors: Malia Cohen, Mark Farrell Attachments: 1. Leg Ver1, 2. Leg Dig Ver1, 3. DRAFT Dev Agrmt, 4. Dev Agrmt Summary 102516, 5. Referral 
CEQA 110116, 6. Referral PC 110116, 7. Referral FYI 110116, 8. Planning Ltr 112816, 9. Executive 
Summary, 10. PC Res 19789, 11. Hearing Notice 011117, 12. CEQA Determination 111716, 13. Form 
126, 14. Bdgt Analyst Rpt 011117, 15. Comm Pkt 011117, 16. Econ Impact Rpt 011017, 17. PPt 
Presentation 011117, 18. Board Pkt 012417, 19. Board Pkt 013117, 20. Form 126 Final, 21. Leg Final
Action By Date Action Result Ver. ASSIGNED UNDER 30 DAY RULE President 10/25/2016 1 REFERRED TO DEPARTMENT Clerk of the Board 11/1/2016 1 RESPONSE RECEIVED Planning Department 11/17/2016 1 TRANSFERRED President 12/13/2016 1 NOTICED Clerk of the Board 12/30/2016 1 RECOMMENDED Budget and Finance Committee 1/11/2017 1 Pass PASSED, ON FIRST READING Board of Supervisors 1/24/2017 1 Pass FINALLY PASSED Board of Supervisors 1/31/2017 1 Pass APPROVED Mayor 2/1/2017 1