logo City Hall
1 Dr. Carlton B. Goodlett 
Place 
San Francisco, CA  94102-
4689
City and County of San Francisco Legislation Details File #:  Version: 1 161204 Name: Urging the Rescission of the Layoff of 156 Hertz 
Corporation Workers
Status: Type: Resolution Passed File created: In control: 11/1/2016 Clerk of the Board On agenda: Final action: 11/23/2016 Enactment date: 483-16 Enactment #: Title: Resolution urging the Hertz Corporation to rescind the layoffs of 156 Hertz Corporation employees  and that these positions remain quality, full-time jobs, and urging the Airport Director Ivar C. Satero  and the Airport Commission to assist the workers in retaining their jobs. Sponsors: Eric Mar, John Avalos, Jane Kim, David Campos, Norman Yee, Aaron Peskin Attachments: 1. Leg Ver1, 2. Board Pkt 111516, 3. Leg Final
Action By Date Action Result Ver. REFERRED FOR ADOPTION WITHOUT 
COMMITTEE REFERENCE AGENDA AT 
THE NEXT BOARD MEETING
President 11/1/2016 1 ADOPTED Board of Supervisors 11/15/2016 1 Pass RETURNED UNSIGNED Mayor 11/23/2016 1