logo City Hall
1 Dr. Carlton B. Goodlett 
Place 
San Francisco, CA  94102-
4689
City and County of San Francisco Legislation Details File #:  Version: 1 161356 Name: Master Development Agreement - Sunnydale 
Development Co., LLC - Sunnydale HOPE SF 
Project
Status: Type: Resolution Passed File created: In control: 12/13/2016 Clerk of the Board On agenda: Final action: 2/3/2017 Enactment date: 2/3/2017 020-17 Enactment #: Title: Resolution authorizing the execution of the Master Development Agreement between the Housing  Authority of the City and County of San Francisco, Sunnydale Development Co., LLC, a California  limited liability company and the City and County of San Francisco, for the Sunnydale HOPE SF  Project at the approximately 50-acre site located in Visitacion Valley and generally bounded by  McLaren Park to the north, Crocker Amazon Park on the west, Hahn Street on the east, and Velasco  on the south; and making findings under the California Environmental Quality Act, and findings of  conformity with the General Plan, and with the eight priority policies of Planning Code, Section 101.1 (b). Sponsors: Malia Cohen, Mark Farrell Attachments: 1. Leg Ver1, 2. Master Dev Agrmt 120616, 3. Hearing Notice 011117, 4. Bdgt Analyst Rpt 011117, 5. 
Comm Pkt 011117, 6. PPt Presentation 011117, 7. Board Pkt 112417, 8. Board Pkt 012417, 9. Leg 
Final
Action By Date Action Result Ver. RECEIVED AND ASSIGNED President 12/13/2016 1 TRANSFERRED President 12/28/2016 1 NOTICED Clerk of the Board 12/30/2016 1 RECOMMENDED Budget and Finance Committee 1/11/2017 1 Pass ADOPTED Board of Supervisors 1/24/2017 1 Pass APPROVED Mayor 2/3/2017 1