logo City Hall
1 Dr. Carlton B. Goodlett 
Place 
San Francisco, CA  94102-
4689
City and County of San Francisco Legislation Details File #:  Version: 2 170267 Name: Agreement Amendment - State Department of 
Health Care Services - Substance Use Disorder 
Services - FYs 2014-2017 - $58,504,385
Status: Type: Resolution Passed File created: In control: 3/21/2017 Clerk of the Board On agenda: Final action: 3/21/2017 5/12/2017 Enactment date: 5/12/2017 158-17 Enactment #: Title: Resolution retroactively authorizing the Department of Public Health, Behavioral Health Services to  enter into Amendment No. A05 to a multi-year agreement for substance use disorder services with the  State Department of Health Care Services, in the amount of $58,504,385 for the term of July 1, 2014,  through June 14, 2017; and authorizing and designating the Department of Public Health County  Alcohol and Drug Administrator to sign said Agreement and to approve amendments for less than  10% of the contracted amount. Sponsors: Attachments: 1. Leg Ver1, 2. Agrmt Amend No. A05 022717, 3. Agrmt Amend No. A04 101316, 4. Agrmt Amend No. 
A03 020816, 5. Agrmt Amend No. A02 062216, 6. Agrmt Amend No. A01 042315, 7. Agrmt No. 14-
90096 101414, 8. Board Reso No. 115-16 040816, 9. DPH Memo 030817, 10. DPH Ltr 030817, 11. 
Bdgt Analyst Rpt 042017, 12. Comm Pkt 042017, 13. DHCS Memo 041117, 14. Leg Ver2, 15. Board 
Pkt 050217, 16. Leg Final
Action By Date Action Result Ver. RECEIVED FROM DEPARTMENT Clerk of the Board 3/9/2017 1 RECEIVED AND ASSIGNED President 3/21/2017 1 AMENDED Budget and Finance Sub-
Committee
4/20/2017 1 Pass RECOMMENDED AS AMENDED Budget and Finance Sub-
Committee
4/20/2017 2 Pass ADOPTED Board of Supervisors 5/2/2017 2 Pass APPROVED Mayor 5/12/2017 2