logo City Hall
1 Dr. Carlton B. Goodlett 
Place 
San Francisco, CA  94102-
4689
City and County of San Francisco Legislation Details File #:  Version: 1 170459 Name: Petitions and Communications Status: Type: Communication Filed File created: In control: 4/17/2017 Clerk of the Board On agenda: Final action: 4/25/2017 Enactment date: Enactment #: Title: Petitions and Communications received from April 10, 2017, through April 17, 2017, for reference by  the President to Committee considering related matters, or to be ordered filed by the Clerk on April 25,  2017. Personal information that is provided in communications to the Board of Supervisors is subject to  disclosure under the California Public Records Act and the San Francisco Sunshine Ordinance.   Personal information will not be redacted. From the Office of the Sheriff, regarding an addendum to Resolution No. 42-17, adopted on January  12, 2017. File No. 170270.  Copy: Each Supervisor. (1) From Clerk of the Board, reporting that the Public Utilities Commission submitted a resolution  adopting schedules of rates and charges for the CleanPowerSF Community Choice Aggregation  Program Rate.  Copy: Each Supervisor. (2) From the Clerk of the Board, reporting that the following individual submitted a Form 700 Statement:  (3) Carolina Morales - Legislative Aide - Assuming From the Office of the Mayor, pursuant to Charter, Section 3.100(18), making the following  appointments: Copy: Each Supervisor. (4) Joseph Alioto Veronese - Fire Commission - term ending January 15, 2020 William K. Cleaveland - Fire Commission - term ending January 15, 2021 From the California Fish and Game Commission, submitting a notice of proposed regulatory action  relative to amending sections 29.80 and 122, Title 14, California Code of Regulations, relating to  upland game bird regulations, which was published in the California Regulatory Notice Register on  April 7, 2017.  Copy: Each Supervisor.  (5) From various City clubs, regarding the appointment of Petra de Jesus to the Police Commission.  Copy: 2 letters. Each Supervisor. (6) From The Harvey Milk LGBT Democratic Club, regarding the appointment of Jordan Davis to the SRO  Taskforce.  Copy: Each Supervisor. (7) From the Office of the Controller, submitting a Citywide Construction audit report.  Copy: Each  Supervisor.  (8) From the Office of the Treasurer and Tax Collector, pursuant to California State Government Code,  Section 53646, submitting a Pooled Investment Report for the month of March 2017.  Copy: Each  Supervisor. (9) From Public Works, submitting an Annual Report for FY 2015-16.  Copy: Each Supervisor. (10) From concerned citizens, regarding the Trump’s Administration’s Executive Order threatening federal  funding for “sanctuary jurisdictions” nationwide.  Copy: Each Supervisor. (11) From Solutions Not Sandbags, regarding sewage discharges into homes and businesses.  Copy:  Each Supervisor (12)
From Bentley Hall, Good Eggs, Inc. applying for a type 21 General Off-Sale License at 901 Rankin  Street. File No. 170428.  (13) From concerned citizens, regarding traffic on 20th Avenue and Judah.  Copy: Each Supervisor. (14) From The Planning Department, reporting that the Planning Department submitted the Extension and  Modification of Commission - Sponsored Mission 2016 Interim Controls Related to the Mission Action  Plan (Map) 2020; and Endorsement of the Mission Action Plan 2020.  Copy: Each Supervisor.  (15) Sponsors: Attachments: 1. Board Pkt 042517
Action By Date Action Result Ver.