logo City Hall
1 Dr. Carlton B. Goodlett 
Place 
San Francisco, CA  94102-
4689
City and County of San Francisco Legislation Details File #:  Version: 7 180646 Name: Environment Code - Refuse Separation Compliance Status: Type: Ordinance Passed File created: In control: 9/11/2018 Clerk of the Board On agenda: Final action: 12/21/2018 Enactment date: 12/21/2018 300-18 Enactment #: Title: Ordinance amending the Environment Code to require audits every three years of large refuse  generators for compliance with refuse separation requirements; to establish enforcement measures  applicable to large refuse generators found noncompliant; and affirming the Planning Department’s  determination under the California Environmental Quality Act. Sponsors: Ahsha Safai, Katy Tang, Hillary Ronen, Vallie Brown Attachments: 1. Leg Ver1, 2. Leg Dig Ver1, 3. Referral CEQA 061918, 4. Referral FYI 061918, 5. Referral SBC 
061918, 6. CEQA Det 070318, 7. Leg Ver2, 8. Leg Dig Ver2, 9. Referral CEQA 091418, 10. Referral 
FYI 091418, 11. Referral SBC 091418, 12. Comm Pkt 091718, 13. CEQA Determination 091718, 14. 
Port Memo 091718, 15. Leg Ver3, 16. Leg Dig Ver3, 17. Referral CEQA 091918, 18. Referral SBC 
091918, 19. Referral FYI 091918, 20. CEQA Determination 092718, 21. BLA Rpt 110118, 22. Comm 
Pkt 110118, 23. SBC Response 102618, 24. Leg Ver4, 25. Leg Dig Ver4, 26. Referral CEQA 110818, 
27. Referral SBC 110818, 28. Referral FYI 110818, 29. BLA Report 111518, 30. Comm Pkt 111518, 
31. CEQA Determination 111318, 32. List of Large Refuse Generators, 33. Leg Ver5, 34. Leg Dig 
Ver5, 35. Comm Pkt 112918, 36. Referral CEQA 112118, 37. Referral SBC 112118, 38. Referral FYI 
112118, 39. BLA Report 112918, 40. CEQA Determination 112818, 41. Leg Ver 6, 42. Leg Dig Ver6, 
43. Bd Pkt 120418, 44. Leg Ver7, 45. Leg Dig Ver7, 46. Board Pkt 121118, 47. Leg Final
Action By Date Action Result Ver. ASSIGNED UNDER 30 DAY RULE President 6/12/2018 1 REFERRED TO DEPARTMENT Clerk of the Board 6/19/2018 1 RESPONSE RECEIVED Planning Department 7/3/2018 1 TRANSFERRED President 7/19/2018 1 SUBSTITUTED AND ASSIGNED President 9/11/2018 2 REFERRED TO DEPARTMENT Clerk of the Board 9/14/2018 2 AMENDED, AN AMENDMENT OF THE 
WHOLE BEARING NEW TITLE
Land Use and Transportation 
Committee
9/17/2018 1 Pass REFERRED AS AMENDED Land Use and Transportation 
Committee
9/17/2018 3 Pass RESPONSE RECEIVED Planning Department 9/17/2018 2 REFERRED TO DEPARTMENT Clerk of the Board 9/19/2018 3 RESPONSE RECEIVED Planning Department 9/27/2018 3 RESPONSE RECEIVED Small Business Commission 10/31/2018 3 CONTINUED AS AMENDED Budget and Finance Committee 11/1/2018 4 Pass AMENDED, AN AMENDMENT OF THE 
WHOLE BEARING SAME TITLE
Budget and Finance Committee 11/1/2018 3 Pass REFERRED TO DEPARTMENT Clerk of the Board 11/8/2018 4 RESPONSE RECEIVED Planning Department 11/13/2018 4 CONTINUED AS AMENDED Budget and Finance Committee 11/15/2018 5 Pass AMENDED, AN AMENDMENT OF THE 
WHOLE BEARING SAME TITLE
Budget and Finance Committee 11/15/2018 4 Pass
REFERRED TO DEPARTMENT Clerk of the Board 11/21/2018 5 RESPONSE RECEIVED Planning Department 11/28/2018 5 RECOMMENDED AS AMENDED AS A 
COMMITTEE REPORT
Budget and Finance Committee 11/29/2018 6 Pass AMENDED, AN AMENDMENT OF THE 
WHOLE BEARING SAME TITLE
Budget and Finance Committee 11/29/2018 5 Pass PASSED ON FIRST READING AS 
AMENDED
Board of Supervisors 12/4/2018 7 Pass AMENDED, AN AMENDMENT OF THE 
WHOLE BEARING SAME TITLE
Board of Supervisors 12/4/2018 5 Pass FINALLY PASSED Board of Supervisors 12/11/2018 7 Pass APPROVED Mayor 12/21/2018 7