logo City Hall
1 Dr. Carlton B. Goodlett 
Place 
San Francisco, CA  94102-
4689
City and County of San Francisco Legislation Details File #:  Version: 2 180858 Name: Resolution of Intent to Vacate Various Streets - 
Sunnydale HOPE SF Project
Status: Type: Resolution Passed File created: In control: 9/4/2018 Clerk of the Board On agenda: Final action: 11/2/2018 Enactment date: 11/2/2018 360-18 Enactment #: Title: Resolution declaring the intention of the Board of Supervisors to order the vacation of streets and  easements in the Sunnydale HOPE SF Project site, generally bounded by Assessor’s Parcel Block  No. 6220 on the north, Velasco Avenue and Assessor’s Parcel Block Nos. 6332 and 6331 on the  south, Assessor’s Parcel Block Nos. 6220 and 6316 on the west, and Hahn Street on the east, as part  of Sunnydale HOPE SF Project, subject to certain conditions; and setting a hearing date for the Board  of Supervisors to sit as a Committee of the Whole on January 15, 2019, for all persons interested in  the proposed vacation of said public right-of-way and easements. Sponsors: Malia Cohen Attachments: 1. Leg Ver1, 2. Comm Pkt 101518, 3. Leg Ver2, 4. Board Pkt 102318, 5. Leg Final, 6. BOS Transmittal 
110918, 7. BOS Transmittal 110918, 8. PG&E Response 022819
Action By Date Action Result Ver. RECEIVED AND ASSIGNED President 9/4/2018 1 AMENDED, AN AMENDMENT OF THE 
WHOLE BEARING NEW TITLE
Land Use and Transportation 
Committee
10/15/2018 1 Pass RECOMMENDED AS AMENDED Land Use and Transportation 
Committee
10/15/2018 2 Pass ADOPTED Board of Supervisors 10/23/2018 2 Pass APPROVED Mayor 11/2/2018 2 TRANSMITTED Clerk of the Board 11/9/2018 2 RESPONSE RECEIVED Clerk of the Board 3/1/2019 2