logo City Hall
1 Dr. Carlton B. Goodlett 
Place 
San Francisco, CA  94102-
4689
City and County of San Francisco Legislation Details File #:  Version: 1 190365 Name: Greater Union Square Business Improvement 
District - Annual Report for FY2017-2018
Status: Type: Resolution Passed File created: In control: 4/2/2019 Clerk of the Board On agenda: Final action: 6/28/2019 Enactment date: 6/28/2019 288-19 Enactment #: Title: Resolution receiving and approving an annual report for the Greater Union Square Business  Improvement District for FY2017-2018, submitted as required by the Property and Business  Improvement District Law of 1994 (California Streets and Highways Code, Sections 36600, et seq.),  Section 36650, and the District’s management agreement with the City, Section 3.4. Sponsors: Aaron Peskin Attachments: 1. Leg Ver1, 2. Annual Rpt FY2017-2018, 3. Financial Statements 063018, 4. OWED Ltr 032219, 5. 
Referral FYI 041019, 6. Comm Pkt 060619, 7. Comm Presentations 060619, 8. Board Pkt 061819, 9. 
Leg Final
Action By Date Action Result Ver. RECEIVED AND ASSIGNED President 4/2/2019 1 REFERRED TO DEPARTMENT Clerk of the Board 4/10/2019 1 RECOMMENDED Government Audit and Oversight 
Committee
6/6/2019 1 Pass ADOPTED Board of Supervisors 6/18/2019 1 Pass APPROVED Mayor 6/28/2019 1