logo City Hall
1 Dr. Carlton B. Goodlett 
Place 
San Francisco, CA  94102-
4689
City and County of San Francisco Legislation Details File #:  Version: 1 190753 Name: Petitions and Communications Status: Type: Communication Filed File created: In control: 7/8/2019 Clerk of the Board On agenda: Final action: 7/16/2019 Enactment date: Enactment #: Title: Petitions and Communications received from July 1, 2019, through July 8, 2019, for reference by the  President to Committee considering related matters, or to be ordered filed by the Clerk on July 16,  2019. Personal information that is provided in communications to the Board of Supervisors is subject to  disclosure under the California Public Records Act and the San Francisco Sunshine Ordinance.  Personal information will not be redacted.  From the Office of the Mayor, pursuant to Charter, Section 4.117, making the following appointment to  the Entertainment Commission: Copy: Each Supervisor. (1) Ben Bleiman - term ending July 1, 2023 From the Office of the Mayor, making the following appointment to the Treasure Island Development  Authority Board of Directors: Copy: Each Supervisor. (2) Ruby Bolaria-Shifrin - term ending February 26, 2022 From the Office of the Mayor, pursuant to Charter, Section 4.106, making the following appointment to  the Board of Appeals: Copy: Each Supervisor. (3) Eduardo Santacana - term ending July 1, 2020 From the Office of the Mayor, pursuant to Charter, Section 3.100, submitting notice designating  Supervisor Stefani as Acting-Mayor from Sunday, June 30, 2019, at 9:46 p.m. until Tuesday, July 2,  2019, at 3:59 p.m.; and Supervisor Mandelman as Acting-Mayor from Tuesday, July 2, 2019, at 4:00  p.m. until Friday, July 5, 2019, at 9:42 p.m. Copy: Each Supervisor. (4) From the Office of the Controller’s City Services Auditor, submitting its Annual Work Plan for FY2019- 2020. Copy: Each Supervisor. (5) From the Office of Contract Monitoring Division, submitting an Administrative Code, Chapter 12B,  Waiver Request. Copy: Each Supervisor. (6) From the Police Department, pursuant to Administrative Code, Section 10.100-305, submitting the  Annual Report on Gifts Received up to $10,000. Copy: Each Supervisor. (7) From the Juvenile Probation Department, pursuant to Administrative Code, Section 12I.5, submitting  the Semi-Annual Report on civil detainers and communications with a Federal agency charged with  enforcement of the Federal immigration law (City Ordinance 12I). Copy: Each Supervisor. (8) From the Department of Aging and Adult Services, submitting the Community Living Fund Annual Plan  for July 2019 to June 2020, the Program for Case Management and Purchase of Resources and  Services Six Month Report: July-Dec 2018. Copy: Each Supervisor. (9) From the Department of Public Health, pursuant to Resolution No. 563-10, submitting the FY2018- 2019 Contingency Report. Copy: Each Supervisor. (10) From Human Services Agency, submitting an Administrative Code, Chapter 12B, Waiver Request. 
Copy: Each Supervisor. (11) From Spencer Hudson, Indivisible SF, regarding President Trump’s comments on the homelessness  crisis. Copy: Each Supervisor. (12) From concerned citizens, regarding Type-21 Liquor License for CloudKitchens, located at 475 6th  Street. 8 letters. File No. 190492. Copy: Each Supervisor. (13) From Erin Archuleta, regarding small business permit streamlining. File No. 181211. Copy: Each  Supervisor. (14) From the Office of Contact Administration, submitting changes to the Minimum Compensation  Ordinance (MCO) and Health Care Accountability Ordinance (HCAO) - Effective July 1, 2019. Copy:  Each Supervisor. (15) From Christopher Kerby, regarding the San Francisco School Board decision to spend $600,000 to  remove a mural. Copy: Each Supervisor. (16) From the Office of the Controller, pursuant to Administrative Code, Chapter 41A, submitting Short- Term Residential Rental Registry Fee - Municipal Code Authorized Fee Increases. Copy: Each  Supervisor. (17) From Ahimsa Porter Sumchai MD, submitting an article she authored, entitled “Houses in the MUD,”  regarding housing at Hunters Point Shipyard. Copy: Each Supervisor. (18) Sponsors: Attachments: 1. Board Pkt 071619
Action By Date Action Result Ver.