logo City Hall
1 Dr. Carlton B. Goodlett 
Place 
San Francisco, CA  94102-
4689
City and County of San Francisco Legislation Details File #:  Version: 4 190845 Name: Development Agreement - Laurel Heights Partners, 
LLC - 3333 California Street Project - California 
Street at Presidio Avenue
Status: Type: Ordinance Passed File created: In control: 9/3/2019 Clerk of the Board On agenda: Final action: 11/27/2019 Enactment date: 11/27/2019 276-19 Enactment #: Title: Ordinance approving a Development Agreement between the City and County of San Francisco and  Laurel Heights Partners, LLC, a Delaware limited liability company, for the development of an  approximately 10.25-acre site located at California Street at Presidio Avenue (3333 California Street),  with various public benefits, including 25% affordable housing, a child care center comprised of  approximately 14,665 square feet, and approximately 2.87 acres of privately owned, publicly  accessible open space; making findings under the California Environmental Quality Act, and findings  of conformity with the General Plan, and the eight priority policies of Planning Code, Section 101.1(b);  approving certain development impact fees for the project, and waiving certain Planning Code fees  and requirements; confirming compliance with or waiving certain provisions of Administrative Code,  Chapter 56; ratifying certain actions taken in connection with the Development Agreement, as  described herein; and authorizing certain actions to be taken under the Development Agreement, as  described herein. Sponsors: Catherine Stefani Attachments: 1. Leg Ver1, 2. Leg Dig Ver1, 3. DRAFT Dev Agrmt, 4. Form 126, 5. Referral PC 080519, 6. Referral 
FYI 080519, 7. Leg Ver2, 8. Leg Dig Ver2, 9. Referral FYI 091119, 10. Referral PC 091119, 11. PC 
Transmittal 091219, 12. Hearing Notice 102119, 13. Updated Dev Agmt 101619, 14. OEWD MOU 
072417, 15. Updated Dev Agmt 101719, 16. Comm Pkt 102119, 17. PLN PPT 102119, 18. Economic 
Impact Rpt 102119, 19. LVMA Letter 102119, 20. Leg Ver3, 21. Leg Dig Ver3, 22. Board Pkt 110519, 
23. Dev Agmt 110719, 24. Board Pkt 111219, 25. Leg Ver4, 26. Leg Dig Ver4, 27. Supplemental 
CEQA Findings, 28. Board Pkt 111919, 29. Form 126 Final, 30. Leg Final
Action By Date Action Result Ver. ASSIGNED UNDER 30 DAY RULE President 7/30/2019 1 REFERRED TO DEPARTMENT Clerk of the Board 8/5/2019 1 SUBSTITUTED AND ASSIGNED President 9/3/2019 2 REFERRED TO DEPARTMENT Clerk of the Board 9/11/2019 2 RESPONSE RECEIVED Planning Commission 9/12/2019 2 NOTICED Clerk of the Board 10/11/2019 2 AMENDED, AN AMENDMENT OF THE 
WHOLE BEARING SAME TITLE
Land Use and Transportation 
Committee
10/21/2019 2 Pass REFERRED WITHOUT 
RECOMMENDATION AS AMENDED
Land Use and Transportation 
Committee
10/21/2019 3 Pass CONTINUED ON FIRST READING Board of Supervisors 11/5/2019 3 Pass AMENDED, AN AMENDMENT OF THE 
WHOLE BEARING SAME TITLE
Board of Supervisors 11/12/2019 3 Pass PASSED ON FIRST READING AS 
AMENDED
Board of Supervisors 11/12/2019 4 Pass FINALLY PASSED Board of Supervisors 11/19/2019 4 Pass APPROVED Mayor 11/27/2019 4