logo City Hall
1 Dr. Carlton B. Goodlett 
Place 
San Francisco, CA  94102-
4689
City and County of San Francisco Legislation Details File #:  Version: 2 190908 Name: Interim Zoning Controls - Conditional Use 
Authorization for Conversion of Residential Care 
Facilities to Other Uses
Status: Type: Resolution Passed File created: In control: 9/3/2019 Clerk of the Board On agenda: Final action: 10/11/2019 Enactment date: 10/11/2019 430-19 Enactment #: Title: Resolution imposing interim zoning controls for 18 months to require a Conditional Use authorization  and specified findings for a proposed change of use from a Residential Care Facility; affirming the  Planning Department’s determination under the California Environmental Quality Act; and making  findings of consistency with the General Plan, and the eight priority policies of Planning Code, Section  101.1. Sponsors: Rafael Mandelman, Norman Yee, Ahsha Safai, Matt Haney, Aaron Peskin, Hillary Ronen, Sandra Lee 
Fewer, Vallie Brown
Attachments: 1. Leg Ver1, 2. Referral CEQA 091019, 3. Hearing Notice 092319, 4. CEQA Determination 091919, 5. 
LTCCC Report 012019, 6. Comm Pkt 092319, 7. Leg Ver2, 8. COB Post Hearing Report 092419, 9. 
Board Pkt 100119, 10. Leg Final, 11. PLN Interim Zoning Six Month Rpt 012921
Action By Date Action Result Ver. ASSIGNED President 9/3/2019 1 REFERRED TO DEPARTMENT Clerk of the Board 9/10/2019 1 NOTICED Clerk of the Board 9/13/2019 1 RESPONSE RECEIVED Planning Department 9/19/2019 1 RECOMMENDED AS AMENDED Land Use and Transportation 
Committee
9/23/2019 2 Pass AMENDED, AN AMENDMENT OF THE 
WHOLE BEARING SAME TITLE
Land Use and Transportation 
Committee
9/23/2019 1 Pass ADOPTED Board of Supervisors 10/1/2019 2 Pass APPROVED Mayor 10/11/2019 2