logo City Hall
1 Dr. Carlton B. Goodlett 
Place 
San Francisco, CA  94102-
4689
City and County of San Francisco Legislation Details File #:  Version: 1 190961 Name: Electrical Code - Repeal of Existing 2016 Code and 
Enactment of 2019 Edition
Status: Type: Ordinance Passed File created: In control: 10/1/2019 Clerk of the Board On agenda: Final action: 10/1/2019 11/21/2019 Enactment date: 11/21/2019 266-19 Enactment #: Title: Ordinance repealing the 2016 Electrical Code in its entirety and enacting a 2019 Electrical Code  consisting of the 2019 California Electrical Code as amended by San Francisco; adopting  environmental findings and findings of local conditions under the California Health and Safety Code;  providing an operative date of January 1, 2020; and directing the Clerk of the Board of Supervisors to  forward the legislation to the California Building Standards Commission as required by State law. Sponsors: Attachments: 1. Leg Ver1, 2. Leg Dig Ver1, 3. DRAFT 2019 SFEC, 4. Exhibit A Findings, 5. 2019 CEC, 6. BIC Ltr 
081219, 7. DBI Ltr 092019, 8. Referral CEQA 100819, 9. CEQA Determination 101519, 10. Comm Pkt 
102819, 11. Board Pkt 110519, 12. Board Pkt 111219, 13. Leg Final, 14. BOS Transmittal 120519
Action By Date Action Result Ver. RECEIVED FROM DEPARTMENT Clerk of the Board 9/23/2019 1 ASSIGNED President 10/1/2019 1 REFERRED TO DEPARTMENT Clerk of the Board 10/8/2019 1 RESPONSE RECEIVED Planning Department 10/15/2019 1 RECOMMENDED Land Use and Transportation 
Committee
10/28/2019 1 Pass PASSED ON FIRST READING Board of Supervisors 11/5/2019 1 Pass FINALLY PASSED Board of Supervisors 11/12/2019 1 Pass APPROVED Mayor 11/21/2019 1 TRANSMITTED Clerk of the Board 12/5/2019 1