logo City Hall
1 Dr. Carlton B. Goodlett 
Place 
San Francisco, CA  94102-
4689
City and County of San Francisco Legislation Details File #:  Version: 1 191117 Name: Urging the State of California to Rescind or Amend 
the Fee-for-Service Pharmacy Reimbursements 
Policy for Specialty Medications
Status: Type: Resolution Passed File created: In control: 10/29/2019 Clerk of the Board On agenda: Final action: 11/5/2019 11/15/2019 Enactment date: 11/15/2019 477-19 Enactment #: Title: Resolution urging the State of California to rescind or amend the new Department of Health Care  Services Medi-Cal policy, regarding fee-for-service pharmacy reimbursements for covered specialty  medications. Sponsors: Hillary Ronen, Rafael Mandelman, Matt Haney, Vallie Brown, Sandra Lee Fewer, Norman Yee, 
Gordon Mar, Ahsha Safai
Attachments: 1. Leg Ver1, 2. Board Pkt 110519, 3. Leg Final, 4. COB Ltrs 112019
Action By Date Action Result Ver. REFERRED FOR ADOPTION WITHOUT 
COMMITTEE REFERENCE AGENDA AT 
THE NEXT BOARD MEETING
President 10/29/2019 1 ADOPTED Board of Supervisors 11/5/2019 1 Pass RETURNED UNSIGNED Mayor 11/15/2019 1 TRANSMITTED Clerk of the Board 11/21/2019 1