logo City Hall
1 Dr. Carlton B. Goodlett 
Place 
San Francisco, CA  94102-
4689
City and County of San Francisco Legislation Details File #:  Version: 1 191185 Name: Port Commission Revenue Bonds - Not to Exceed 
$27,000,000
Status: Type: Resolution Passed File created: In control: 11/19/2019 Clerk of the Board On agenda: Final action: 1/31/2020 Enactment date: 1/31/2020 032-20 Enactment #: Title: Resolution authorizing the issuance of Port Commission of the City and County of San Francisco  Refunding Revenue Bonds, Series 2020, in an aggregate principal amount not to exceed $27,000,000  to refund outstanding Series 2010A and Series 2010B revenue bonds of the Port; approving the form  of a third supplement to the indenture of trust; approving the form of a Bond Purchase Contract  relating to the Refunding Bonds; approving the form of an Official Statement in preliminary and final  form relating to the Refunding Bonds; approving the forms of Escrow Agreements; approving the form  of a Continuing Disclosure Certificate; granting general authority to City officials to take necessary  actions in connection with the authorization, sale, execution and delivery of the Bonds; approving  modifications to documents relating thereto; and approving other related matters, as defined herein. Sponsors: Mayor Attachments: 1. Leg Ver1, 2. DRAFT 3rd Supp Indenture of Trust 092019, 3. DRAFT Purchase Contract 100819, 4. 
DRAFT Prelim Official Statement 100819, 5. DRAFT Escrow Deposit and Trust Agrmt Series 2010A 
082319, 6. DRAFT Escrow Deposit and Trust Agrmt Series 2010B 082319, 7. DRAFT Form of Cont 
Disclosure Cert, 8. Port Reso No. 19-42 102219, 9. Port Memo 111519, 10. BLA 011520, 11. Comm 
Pkt 011520, 12. PPt Presentation 011520, 13. Board Pkt 012820, 14. Leg Final
Action By Date Action Result Ver. RECEIVED AND ASSIGNED President 11/19/2019 1 RECOMMENDED Budget and Finance Committee 1/15/2020 1 Pass ADOPTED Board of Supervisors 1/28/2020 1 Pass APPROVED Mayor 1/31/2020 1