logo City Hall
1 Dr. Carlton B. Goodlett 
Place 
San Francisco, CA  94102-
4689
City and County of San Francisco Legislation Details File #:  Version: 2 200043 Name: Lease of Real Property - TC II 888 Post, LLC - 888 
Post Street - Base Annual Rent $1,500,000 - 
Landlord Work $5,000,000
Status: Type: Resolution Passed File created: In control: 1/14/2020 Clerk of the Board On agenda: Final action: 2/28/2020 Enactment date: 2/28/2020 071-20 Enactment #: Title: Resolution approving and authorizing the Director of Property, on behalf of the Department of  Homelessness and Supportive Housing, to lease real property located at 888 Post Street, for an initial  term of 20 years anticipated to commence on October 1, 2020, from TC II 888 Post, LLC, at a base  rent of $1,500,000 per year, increasing at 3% per year; authorizing the City’s contribution of up to  $5,000,000 towards the cost of landlord work; authorizing the Director of Property, under certain  conditions, to negotiate and enter into future subleases, including with Goodwill Industries of San  Francisco, San Mateo and Marin Counties, Inc. as a subtenant; authorizing the Director of Property to  execute documents, make certain modifications and take certain actions in furtherance of the Lease  and this Resolution, as defined herein, including allowing the City to increase its contribution towards  the cost of the landlord work, subject to future appropriation of funds, as defined herein; finding the  proposed transaction is in conformance with the General Plan, and the eight priority policies of  Planning Code, Section 101.1; and adopting findings under the California Environmental Quality Act. Sponsors: Mayor, Aaron Peskin, Matt Haney, Shamann Walton, Ahsha Safai, Dean Preston Attachments: 1. Leg Ver1, 2. DRAFT Lease, 3. Referral - CEQA 013020, 4. BLA Report 021220, 5. Comm Pkt 
021220, 6. CEQA Determination 021120, 7. PLN - GPR Letter 021120, 8. PPt Presentation 021220, 9. 
Leg Ver2, 10. Form 126, 11. Board Pkt 022520, 12. Leg Final, 13. Form 126 Final
Action By Date Action Result Ver. RECEIVED AND ASSIGNED President 1/14/2020 1 REFERRED TO DEPARTMENT Clerk of the Board 1/30/2020 1 RESPONSE RECEIVED Planning Department 2/11/2020 1 RECOMMENDED AS AMENDED Budget and Finance Committee 2/12/2020 2 Pass AMENDED, AN AMENDMENT OF THE 
WHOLE BEARING NEW TITLE
Budget and Finance Committee 2/12/2020 1 Pass ADOPTED Board of Supervisors 2/25/2020 2 Pass APPROVED Mayor 2/28/2020 2