logo City Hall
1 Dr. Carlton B. Goodlett 
Place 
San Francisco, CA  94102-
4689
City and County of San Francisco Legislation Details File #:  Version: 1 200220 Name: Commending the California State Assembly - House 
Resolution No. 77 (Muratsuchi) - Apology for World 
War II Japanese American Internment Camps
Status: Type: Resolution Passed File created: In control: 2/25/2020 Clerk of the Board On agenda: Final action: 3/13/2020 Enactment date: 3/13/2020 087-20 Enactment #: Title: Resolution commending the California State Assembly for passing House Resolution No. 77, authored  by Assembly Member Al Muratsuchi, issuing a formal apology to all Americans of Japanese ancestry  for the unjust exclusion, removal, and incarceration of Japanese Americans in World War II internment  camps. Sponsors: Sandra Lee Fewer, Norman Yee, Shamann Walton, Matt Haney, Rafael Mandelman, Dean Preston, 
Aaron Peskin, Hillary Ronen, Ahsha Safai, Catherine Stefani, Gordon Mar
Attachments: 1. Leg Ver1, 2. Board Pkt 030320, 3. Leg Final
Action By Date Action Result Ver. REFERRED FOR ADOPTION WITHOUT 
COMMITTEE REFERENCE AGENDA AT 
THE NEXT BOARD MEETING
President 2/25/2020 1 ADOPTED Board of Supervisors 3/3/2020 1 Pass RETURNED UNSIGNED Mayor 3/13/2020 1