logo City Hall
1 Dr. Carlton B. Goodlett 
Place 
San Francisco, CA  94102-
4689
City and County of San Francisco Legislation Details File #:  Version: 1 200222 Name: Urging Invalidation of 2019 Revenue Agreement - 
JC Decaux
Status: Type: Resolution Filed File created: In control: 2/25/2020 Government Audit and Oversight Committee On agenda: Final action: 11/29/2021 Enactment date: Enactment #: Title: Resolution urging Public Works and the Office of the City Attorney to take immediate steps to cancel  the City and County of San Francisco’s Revenue Agreement with JC Decaux, including ceasing  implementation of its lucrative Grant of Advertising Rights. Sponsors: Aaron Peskin, Matt Haney, Gordon Mar Attachments: 1. Leg Ver1, 2. Board Pkt 030320, 3. Comm Pkt 070220, 4. JCDecaux Ltr 063020, 5. CCO Ltr 
070720, 6. Comm Pkt 071720, 7. PW Ltr 071620, 8. RFP1, 9. RFP2, 10. JCDeaux Letter 071620
Action By Date Action Result Ver. REFERRED FOR ADOPTION WITHOUT 
COMMITTEE REFERENCE AGENDA AT 
THE NEXT BOARD MEETING
President 2/25/2020 1 REFERRED Board of Supervisors 3/3/2020 1 Pass CONTINUED TO CALL OF THE CHAIR Government Audit and Oversight 
Committee
7/2/2020 1 Pass CONTINUED TO CALL OF THE CHAIR Government Audit and Oversight 
Committee
7/17/2020 1 Pass REMAIN ACTIVE Clerk of the Board 2/1/2021 1 FILED PURSUANT TO RULE 3.41 Clerk of the Board 11/29/2021 1