logo City Hall
1 Dr. Carlton B. Goodlett 
Place 
San Francisco, CA  94102-
4689
City and County of San Francisco Legislation Details File #:  Version: 1 200388 Name: Petitions and Communications Status: Type: Communication Filed File created: In control: 4/16/2020 Clerk of the Board On agenda: Final action: 4/21/2020 Enactment date: Enactment #: Title: Petitions and Communications received from April 9, 2020, through April 16, 2020, for reference by  the President to Committee considering related matters, or to be ordered filed by the Clerk on April 21,  2020. Personal information that is provided in communications to the Board of Supervisors is subject to  disclosure under the California Public Records Act and the San Francisco Sunshine Ordinance.  Personal information will not be redacted.  From the Office of the Mayor, making three nominations to the following agencies: Copy: Each  Supervisor. (1) Pursuant to Charter, Section 8A.102: Janie Natoli - Municipal Transportation Agency Board of Directors, term ending March 1, 2024 (File No. 200389) Pursuant to California Health & Safety Code, Section 34179(a)(10): Anna Van Degna - Redevelopment Successor Agency Oversight Board, term ending January 24, 2022 (File No. 200391) Lydia Ely - Redevelopment Successor Agency Oversight Board, term ending January 24, 2024 (File No. 200390) From the Office of the Mayor, submitting supplements to the Mayoral Proclamation Declaring the  Existence of a Local Emergency, dated February 25, 2020. Copy: Each Supervisor. (2) From the Office of the Mayor, submitting authorizations for committee meeting waivers. 2 letters.  Copy: Each Supervisor. (3) From the Department of Homelessness and Supportive Housing, submitting an update on the spread  of COVID-19 in shelters. Copy: Each Supervisor. (4) From the Office of the Mayor, pursuant to the Eighth Supplement to the Mayoral Proclamation  Declaring the Existence of a Local Emergency dated February 25, 2020, submitting an Executive  Order extending the commercial eviction moratorium. Copy: Each Supervisor. (5)  From the Office of the Treasurer and Tax Collector, pursuant to California State Government Code,  Section 53646, submitting the CCSF Pooled Investment Report, March 2020. Copy: Each Supervisor.  (6) From the Municipal Transportation Agency, regarding the new program subsidizing essential trips by  taxi for people with disabilities and older adults. Copy: Each Supervisor. (7) From the Office of Small Business, submitting a copy of the letter they submitted to Mayor Breed  regarding recommendations for the fourth and subsequent Federal Economic Stimulus Packages.  Copy: Each Supervisor. (8) From the Public Utilities Commission, pursuant to Ordinance No. 32-20, submitting the fully executed  Amended and Restated Conditional Land Disposition and Acquisition Agreement, dated February 28,  2020. Copy: Each Supervisor. (9)
From the Office of the Public Defender, regarding the press statement noting the first confirmed case  of Coronavirus in the County Jail. Copy: Each Supervisor. (10) From Zacks, Freedman and Patterson, regarding the proposed Ordinance amending the Planning  Code, Zoning Map, for the Bayview Industrial Redevelopment Project. File No. 200086. Copy: Each  Supervisor. (11) From concerned citizen, regarding the proposed Ordinance amending the Planning Code to create  the Geary-Masonic Special Use District. File No. 191002. Copy: Each Supervisor. (12) From the Office of the Public Defender, submitting a statement regarding the proposed Emergency  Ordinance on limiting COVID-19 impacts through safe shelter options. File No. 200363. Copy: Each  Supervisor. (13) From concerned citizens, regarding the proposed Emergency Ordinance on limiting COVID-19  impacts through safe shelter options. File No. 200363. 71 letters. Copy: Each Supervisor. (14) From concerned citizens, regarding people experiencing homelessness. 4 letters. Copy: Each  Supervisor. (15)   From concerned citizens, regarding the Hearing on criminal justice reform and the closure of County  Jail No. 4. File No. 200248. 38 letters. Copy: Each Supervisor. (16) From Anonymous, regarding decisions by the Sunshine Ordinance Task Force that Mayor Breed and  City Attorney Herrera were found in violation of the Sunshine Ordinance. Copy: Each Supervisor. (17) From concerned citizens, regarding COVID-19. 7 letters. Copy: Each Supervisor. (18) From concerned citizen, regarding the proposed Balboa Reservoir Development. Copy: Each  Supervisor. (19) From the Sierra Club, regarding the Planning Department’s plan to modify the California  Environmental Quality Act (CEQA) approval process in San Francisco. Copy: Each Supervisor. (20) From the Anti Displacement Coalition, regarding recommendations to update the eviction moratorium.  2 letters. Copy: Each Supervisor. (21) From concerned citizen, regarding the proposed Emergency Ordinance on public health emergency  leave. File No. 200355. Copy: Each Supervisor. (22) From concerned citizen, regarding the proposed Resolution urging the Governor to expedite the  procurement of equipment and ventilators. File No. 200368. Copy: Each Supervisor. (23) From concerned citizen, regarding the proposed Emergency Ordinance on grocery store, drug store,  restaurant, and on-demand delivery service employee protections. File No. 200360. Copy: Each  Supervisor. (24) From concerned citizen, regarding the proposed Resolution declaring Jack and Jane Morrison Day on  April 17, 2020. File No. 200367. Copy: Each Supervisor. (25) From concerned citizens, regarding the proposed Resolution urging the Municipal Transportation  Agency to refrain from any Muni fare increases. File No. 200147. 9 letters. Copy: Each Supervisor.  (26) From concerned citizen, regarding a proposed Charter Amendment that would affect City and County  employees who retired pre-1996. Copy: Each Supervisor. (27)  From concerned citizen, regarding a suggestion for the Department of Building Inspection to accept  online submittals and plan checks during the COVID-19 crisis. Copy: Each Supervisor. (28) From various businesses, pursuant to WARN Act, California Labor Code, Section 1401, submitting  notice of plant closure and/or mass layoffs. 4 letters. Copy: Each Supervisor. (29) Sponsors: Attachments: 1. Board Pkt 042120
Action By Date Action Result Ver.