logo City Hall
1 Dr. Carlton B. Goodlett 
Place 
San Francisco, CA  94102-
4689
City and County of San Francisco Legislation Details File #:  Version: 1 200588 Name: Greater Union Square Business Improvement 
District - Annual Report for FY2018-2019
Status: Type: Resolution Passed File created: In control: 6/2/2020 Clerk of the Board On agenda: Final action: 9/25/2020 Enactment date: 9/25/2020 392-20 Enactment #: Title: Resolution receiving and approving annual report for the Greater Union Square Business  Improvement District for Fiscal Year 2018-2019, submitted as required by the Property and Business  Improvement District Law of 1994 (California Streets and Highways Code, Sections 36600, et seq.),  Section 36650, and the District’s management agreement with the City, Section 3.4. Sponsors: Aaron Peskin Attachments: 1. Leg Ver1, 2. Annual Report FY2018-2019, 3. Financial Statement FY2018-2019, 4. OEWD Memo 
060220, 5. FYI Referral 061020, 6. Comm Pkt 090320, 7. OEWD Presentation 090320, 8. Board Pkt 
091520, 9. Leg Final
Action By Date Action Result Ver. RECEIVED AND ASSIGNED President 6/2/2020 1 REFERRED TO DEPARTMENT Clerk of the Board 6/10/2020 1 RECOMMENDED Government Audit and Oversight 
Committee
9/3/2020 1 Pass ADOPTED Board of Supervisors 9/15/2020 1 Pass APPROVED Mayor 9/25/2020 1