logo City Hall
1 Dr. Carlton B. Goodlett 
Place 
San Francisco, CA  94102-
4689
City and County of San Francisco Legislation Details File #:  Version: 1 200822 Name: Japantown Community Benefit District - Annual 
Report - FY2018-2019
Status: Type: Resolution Passed File created: In control: 7/28/2020 Clerk of the Board On agenda: Final action: 12/11/2020 Enactment date: 12/11/2020 537-20 Enactment #: Title: Resolution receiving and approving annual report for the Japantown Community Benefit District for  Fiscal Year (FY) 2018-2019, submitted as required by the Property and Business Improvement District  Law of 1994 (California Streets and Highways Code, Sections 36600, et seq.), Section 36650, and the  District’s management agreement with the City, Section 3.4. Sponsors: Dean Preston Attachments: 1. Leg Ver1, 2. Annual Report FY2018-2019, 3. Financial Statements 063018, 4. OWED Memo 
062320, 5. FYI Referral 080520, 6. Comm Pkt 111920, 7. OEWD Presentation 111920, 8. Board Pkt 
120120, 9. Leg Final
Action By Date Action Result Ver. RECEIVED AND ASSIGNED President 7/28/2020 1 REFERRED TO DEPARTMENT Clerk of the Board 8/5/2020 1 RECOMMENDED Government Audit and Oversight 
Committee
11/19/2020 1 Pass ADOPTED Board of Supervisors 12/1/2020 1 Pass APPROVED Mayor 12/11/2020 1