logo City Hall
1 Dr. Carlton B. Goodlett 
Place 
San Francisco, CA  94102-
4689
City and County of San Francisco Legislation Details File #:  Version: 1 201016 Name: Modification of Easement Deed - Koret Foundation - 
SFPUC Parcel 22 - Located in South San 
Francisco, California
Status: Type: Resolution Passed File created: In control: 9/15/2020 Clerk of the Board On agenda: Final action: 9/15/2020 10/16/2020 Enactment date: 10/16/2020 490-20 Enactment #: Title: Resolution approving the First Amendment to Easement Deed between the Koret Foundation and the  City and County of San Francisco, acting by and through its San Francisco Public Utilities  Commission (SFPUC), for the purpose of clarifying and amending the respective rights of the parties  to the Grant Deed, dated April 6, 1907, (Original Deed) with respect to SFPUC Parcel 22 located  between West Orange Avenue and Southwood Drive in South San Francisco, California; and  authorizing the Director of Property and/or the SFPUC’s General Manager to execute documents,  make certain modifications, and take certain actions in furtherance of this Resolution, as defined  herein. Sponsors: Attachments: 1. PULeg Ver1, 2. DRAFT Deed Amendment, 3. PUC Reso No.  20-0137 062320, 4. Century Urban 
Economic Report 030920, 5. Original Deed 1907, 6. Koret Foundation Lease 010700, 7. PUC Ltr 
090420, 8. Comm Pkt 093020, 9. PPt Presentation 093020, 10. Board Pkt 100620, 11. Leg Final
Action By Date Action Result Ver. RECEIVED FROM DEPARTMENT Clerk of the Board 9/4/2020 1 RECEIVED AND ASSIGNED President 9/15/2020 1 RECOMMENDED Budget and Finance Committee 9/30/2020 1 Pass ADOPTED Board of Supervisors 10/6/2020 1 Pass APPROVED Mayor 10/16/2020 1