logo City Hall
1 Dr. Carlton B. Goodlett 
Place 
San Francisco, CA  94102-
4689
City and County of San Francisco Legislation Details File #:  Version: 3 201260 Name: Fee and Tax Relief for Certain Businesses Status: Type: Ordinance Passed File created: In control: 12/8/2020 Clerk of the Board On agenda: Final action: 1/22/2021 Enactment date: 1/22/2021 008-21 Enactment #: Title: Ordinance waiving certain license fees originally due on March 31, 2020, and March 31, 2021,  business registration fees for the fiscal years beginning July 1, 2020, and July 1, 2021, and payroll  expense taxes for the tax year beginning January 1, 2020, for businesses with no more than  $20,000,000 in San Francisco gross receipts holding a place of entertainment permit; waiving certain  license fees originally due on March 31, 2020, business registration fees for the fiscal year beginning  July 1, 2020, and payroll expense taxes for the tax year beginning January 1, 2020, for businesses  with no more than $750,000 in San Francisco gross receipts holding a restaurant permit; refunding  any waived amounts paid to the City; extending the deadline to pay license fees originally due on  March 31, 2020, and March 31, 2021, to November 1, 2021; extending the deadline to pay business  registration fees originally due on June 1, 2020, to April 30, 2021; and extending the deadline to pay  and file returns for certain business taxes for the 2020 tax year to April 30, 2021. Sponsors: Mayor, Rafael Mandelman, Catherine Stefani, Gordon Mar, Shamann Walton, Hillary Ronen, Matt 
Haney, Sandra Lee Fewer, Ahsha Safai, Dean Preston
Attachments: 1. Leg Ver1, 2. Leg Dig Ver1, 3. SBC Referral 110920, 4. Referral 110920, 5. Leg Ver2, 6. Leg Dig 
Ver2, 7. Sup Walton Co-Sponsorhip Req, 8. Sup Ronen Co-Sponsorhip Req, 9. Referral 120720, 10. 
SBC Referral 120720, 11. Leg Ver3, 12. Leg Dig Ver3, 13. BLA Report 121620, 14. OEA Response on 
Econ Impact, 15. Memo - BOS President and Budget Chair 121020, 16. Comm Pkt 121620, 17. 
Referral 121420, 18. SBC Referral 121420, 19. Sup Haney Co-Sponsorhip Req, 20. Board Pkt 
010521, 21. Board Pkt 011221, 22. SBC Response 011421, 23. Leg Final
Action By Date Action Result Ver. ASSIGNED UNDER 30 DAY RULE President 11/3/2020 1 REFERRED TO DEPARTMENT Clerk of the Board 11/9/2020 1 SUBSTITUTED AND ASSIGNED UNDER 
30 DAY RULE
President 12/1/2020 2 REFERRED TO DEPARTMENT Clerk of the Board 12/7/2020 2 SUBSTITUTED AND ASSIGNED President 12/8/2020 3 REFERRED TO DEPARTMENT Clerk of the Board 12/14/2020 3 RECOMMENDED Budget and Finance Committee 12/16/2020 3 Pass PASSED ON FIRST READING Board of Supervisors 1/5/2021 3 Pass FINALLY PASSED Board of Supervisors 1/12/2021 3 Pass APPROVED Mayor 1/22/2021 3