logo City Hall
1 Dr. Carlton B. Goodlett 
Place 
San Francisco, CA  94102-
4689
City and County of San Francisco Legislation Details File #:  Version: 1 041542 Name: Hunters Point Shipyard- Resolution of Intent for 
Street Vacation
Status: Type: Resolution Passed File created: In control: 11/2/2004 Board of Supervisors On agenda: Final action: 12/14/2004 Enactment date: 734-04 Enactment #: Title: Resolution declaring the intention of the Board of Supervisors to vacate portions of McKinnon Avenue,  La Salle Avenue, Kirkwood Avenue, Jerrold Avenue, Innes Avenue, Hudson Avenue,  Boalt Street,  Coleman Street, Donahue Street, and Galvez Street in Hunters Point Shipyard Parcel “A1” and  Oakdale Avenue, Newcomb Avenue, McKinnon Avenue, La Salle Avenue, Fitch Street, and Earl  Street in Hunters Point Shipyard Parcel “A2” along with public service easements in the  aforementioned  locations in the Hunters Point Shipyard; setting a hearing date of January 11, 2005 at  3:00 p.m. for all persons interested in the proposed vacation of said street areas and public service  easements. Sponsors: Mayor, Sophie Maxwell Attachments: 1. Leg_Ver1, 2. Leg_Ver2, 3. Leg_Final
Action By Date Action Result Ver. RECEIVED AND ASSIGNED President 11/2/2004 1 AMENDED, AN AMENDMENT OF THE 
WHOLE BEARING NEW TITLE
Land Use Committee 12/6/2004 1 RECOMMENDED AS AMENDED AS A 
COMMITTEE REPORT
Land Use Committee 12/6/2004 2 Pass CONTINUED Board of Supervisors 12/7/2004 1 Pass ADOPTED Board of Supervisors 12/14/2004 1 Pass APPROVED Mayor 12/14/2004 1