logo City Hall
1 Dr. Carlton B. Goodlett 
Place 
San Francisco, CA  94102-
4689
City and County of San Francisco Legislation Details File #:  Version: 1 210497 Name: Planning Code and Zoning Map - Delete Life 
Science and Medical Special Use District
Status: Type: Ordinance Passed File created: In control: 5/4/2021 Clerk of the Board On agenda: Final action: 11/12/2021 Enactment date: 11/12/2021 202-21 Enactment #: Title: Ordinance amending the Planning Code and Zoning Map to eliminate the Life Science and Medical  Special Use District; affirming the Planning Department’s determination under the California  Environmental Quality Act; making findings of consistency with the General Plan, and the eight priority  policies of Planning Code, Section 101.1; and adopting findings of public necessity, convenience, and  welfare under Planning Code, Section 302. Sponsors: Shamann Walton Attachments: 1. Leg Ver1, 2. Leg Dig Ver1, 3. Referral CEQA 051221, 4. Referal PC 051221, 5. PLN Exec 
Summary 072221, 6. PLN Reso No. 20943, 7. PLN Transmittal 080521, 8. Hearing Notice 101821, 9. 
Comm Pkt 101821, 10. Public Comment 101821, 11. Board Pkt 102621, 12. Board Pkt 110221, 13. 
Leg Final, 14. BOS Transmittal 111721
Action By Date Action Result Ver. ASSIGNED UNDER 30 DAY RULE President 5/4/2021 1 REFERRED TO DEPARTMENT Clerk of the Board 5/12/2021 1 RESPONSE RECEIVED Planning Commission 8/23/2021 1 NOTICED Clerk of the Board 10/8/2021 1 RECOMMENDED Land Use and Transportation 
Committee
10/18/2021 1 Pass PASSED ON FIRST READING Board of Supervisors 10/26/2021 1 Pass FINALLY PASSED Board of Supervisors 11/2/2021 1 Pass APPROVED Mayor 11/12/2021 1 TRANSMITTED Clerk of the Board 11/17/2021 1