logo City Hall
1 Dr. Carlton B. Goodlett 
Place 
San Francisco, CA  94102-
4689
City and County of San Francisco Legislation Details File #:  Version: 1 210614 Name: Union Square Business Improvement District - 
Annual Report - FY2019-2020
Status: Type: Resolution Passed File created: In control: 5/25/2021 Clerk of the Board On agenda: Final action: 11/12/2021 Enactment date: 11/12/2021 514-21 Enactment #: Title: Resolution receiving and approving the annual report for the Greater Union Square Business  Improvement District for Fiscal Year (FY) 2019-2020, submitted as required by the Property and  Business Improvement District Law of 1994 (California Streets and Highways Code, Sections 36600,  et seq.), Section 36650, and the District’s management agreement with the City, Section 3.4. Sponsors: Aaron Peskin Attachments: 1. Leg Ver1, 2. Annual Report FY2019-2020, 3. CPA Rpt 063020, 4. OEWD Memo 052421, 5. FYI 
Referral 060221, 6. Comm Pkt 102121, 7. OEWD Presentation 102121, 8. Board Pkt 110221, 9. Leg 
Final
Action By Date Action Result Ver. RECEIVED AND ASSIGNED President 5/25/2021 1 REFERRED TO DEPARTMENT Clerk of the Board 6/2/2021 1 RECOMMENDED Government Audit and Oversight 
Committee
10/21/2021 1 Pass ADOPTED Board of Supervisors 11/2/2021 1 Pass APPROVED Mayor 11/12/2021 1