logo City Hall
1 Dr. Carlton B. Goodlett 
Place 
San Francisco, CA  94102-
4689
City and County of San Francisco Legislation Details File #:  Version: 1 211001 Name: Real Property Sale Agreement - State of California - 
Portions of SFPUC Parcel No. 65 - State Route 84 / 
Interstate 680 Widening Project in Alameda County 
- $152,952
Status: Type: Resolution Passed File created: In control: 9/28/2021 Clerk of the Board On agenda: Final action: 9/28/2021 11/12/2021 Enactment date: 11/12/2021 517-21 Enactment #: Title: Resolution 1) approving and authorizing the General Manager of the San Francisco Public Utilities  Commission (“SFPUC”) and/or the Director of Property, on behalf of the City and County of San  Francisco (“City”), to sell certain real property located along State Route 84 and Interstate 680 in  unincorporated Alameda County to the State of California (Parcel No. 65) for public highway  improvements, acting through its California Department of Transportation (“Caltrans”), and the  Alameda County Transportation Commission (“Alameda CTC” and together with Caltrans, the  “Buyers”) for the amount of $152,952; 2) approving and authorizing an Agreement for Sale of Real  Estate (“Sale Agreement”) for the sale of the Property to the Buyers, which includes a liquidated  damages clause in case of default by the City; 3) authorizing the SFPUC General Manager and/or  City’s Director of Property to execute the Sale Agreement, make certain modifications, and take  certain actions in furtherance of this Resolution and the Sale Agreement, as defined herein; 4)  adopting findings declaring that the real property is “surplus land” and “exempt surplus land” pursuant  to the California Surplus Lands Act; 5) determining that a competitive bidding process for the  conveyance of the Property is impractical and not in the public interest, in accordance with Section  23.3 of the Administrative Code; 6) affirming the Planning Department’s determination under the  California Environmental Quality Act (“CEQA”) and adopting the findings required by Section 15091 of  the CEQA Guidelines previously adopted by Caltrans in conjunction with the Project; and 7) adopting  the Planning Department’s findings that the Sale Agreement, and the transaction contemplated  therein, is consistent with the General Plan, and the eight priority policies of Planning Code, Section  101.1. Sponsors: Attachments: 1. Leg Ver1, 2. DRAFT Sale Agrmt, 3. PUC Reso No. 21-0110 071321, 4. PUC Executed Declaration 
052021, 5. PUC Approval of Property Appraisals, 6. CEQA NEPA Revalidation 071320, 7. PLN Gen 
Pln Ref 050521, 8. PUC Memo 091721, 9. Comm Pkt 102721, 10. Pres Action Memo 102621, 11. 
Board Pkt 110221, 12. Leg Final, 13. Final PSA - executed by City, 14. Final PSA - executed by 
Caltrans ACTC
Action By Date Action Result Ver. RECEIVED FROM DEPARTMENT Clerk of the Board 9/17/2021 1 RECEIVED AND ASSIGNED President 9/28/2021 1 RECOMMENDED Budget and Finance Committee 10/27/2021 1 Pass ADOPTED Board of Supervisors 11/2/2021 1 Pass APPROVED Mayor 11/12/2021 1 RESPONSE RECEIVED Public Utilities Commission 2/23/2022 1