logo City Hall
1 Dr. Carlton B. Goodlett 
Place 
San Francisco, CA  94102-
4689
City and County of San Francisco Legislation Details File #:  Version: 1 211240 Name: Apologizing to Chinese Immigrants and Their 
Descendants
Status: Type: Resolution Passed File created: In control: 11/30/2021 Clerk of the Board On agenda: Final action: 2/11/2022 Enactment date: 2/11/2022 039-22 Enactment #: Title: Resolution apologizing on behalf of the Board of Supervisors of the City and County of San Francisco  to Chinese immigrants and their descendants for systemic and structural discrimination, targeted acts  of violence, and atrocities; and committing to the rectification and redress of past policies and  misdeeds. Sponsors: Matt Haney, Shamann Walton, Ahsha Safai, Gordon Mar, Catherine Stefani, Rafael Mandelman Attachments: 1. Leg Ver1, 2. Presidential Action Memo 122921, 3. Cmte Pkt 012622, 4. Board Pkt 020122, 5. Leg 
Final
Action By Date Action Result Ver. RECEIVED AND ASSIGNED President 11/30/2021 1 TRANSFERRED President 12/29/2021 1 RECOMMENDED Budget and Finance Committee 1/26/2022 1 Pass ADOPTED Board of Supervisors 2/1/2022 1 Pass APPROVED Mayor 2/11/2022 1