logo City Hall
1 Dr. Carlton B. Goodlett 
Place 
San Francisco, CA  94102-
4689
City and County of San Francisco Legislation Details File #:  Version: 1 220442 Name: Report of Delinquent Administrative Civil Penalties 
and Recovery of Costs for Violations - Unauthorized 
Releases of Hazardous Material(s)
Status: Type: Resolution Passed File created: In control: 5/3/2022 Clerk of the Board On agenda: Final action: 5/3/2022 6/3/2022 Enactment date: 6/3/2022 243-22 Enactment #: Title: Resolution confirming report of delinquent charges for overdue Administrative Civil Penalties and  recovery of costs for violations of Health Code, Article 21, the unauthorized releases of hazardous  material(s), observed at Assessor’s Parcel Block No. 0798, Lot No. 031 (930 Grove Street), submitted  by the Director of Public Health, as modified to the date of adoption of this Resolution, and creating  special assessments and liens based thereon. Sponsors: Attachments: 1. Leg Ver1, 2. DPH Lien Rpt 042222, 3. Board Pkt 052422, 4. Post Pkt Public Correspondence, 5. 
Leg Final, 6. Recorded Reso 061322, 7. COB Ltr 061422
Action By Date Action Result Ver. RECEIVED FROM DEPARTMENT Clerk of the Board 4/22/2022 1 RECEIVED AND ASSIGNED President 5/3/2022 1 ADOPTED Board of Supervisors 5/24/2022 1 Pass APPROVED Mayor 6/3/2022 1 RECORDED Clerk of the Board 6/13/2022 1