logo City Hall
1 Dr. Carlton B. Goodlett 
Place 
San Francisco, CA  94102-
4689
City and County of San Francisco Legislation Details File #:  Version: 1 220657 Name: Sale Agreement - Santa Clara Valley Water District - 
10,925 Square Feet of Portion of APN 104-28-066 
in Sunnyvale, Santa Clara County - $33,000
Status: Type: Resolution Passed File created: In control: 6/7/2022 Clerk of the Board On agenda: Final action: 6/7/2022 8/4/2022 Enactment date: 8/4/2022 350-22 Enactment #: Title: Resolution 1) approving and authorizing the sale to Santa Clara Valley Water District for $33,000 of  approximately 10,925 square feet of real property located near Manzano Way in Sunnyvale,  California, a portion of Assessor’s Parcel No. (APN) 104-28-066; 2) adopting findings declaring that  the property is “surplus land” and “exempt surplus land” pursuant to the California Surplus Lands Act;  3) adopting findings under Administrative Code, Section 23.3, that offering the property for sale  through competitive bidding would be impractical and not in the public interest; 4) affirming the  Planning Department’s determination under the California Environmental Quality Act; 5) adopting  findings that the sale of the property is consistent with the General Plan, and the eight priority policies  of Planning Code, Section 101.1; and 6) authorizing the San Francisco Public Utilities Commission  (SFPUC) General Manager and/or City’s Director of Property to execute documents, make certain  modifications, and take certain actions in furtherance of this Resolution, as defined herein; and to  authorize the SFPUC General Manager and/or City’s Director of Property to enter into any additions,  amendments, or other modifications to the Sale Agreement that do not materially decrease the  benefits to the City with respect to the Property, and do not materially increase the obligations or  liabilities of either the SFPUC or the City, and are necessary or advisable to complete the transaction  contemplated in the Sale Agreement, to effectuate the purpose and intent of this Resolution. Sponsors: Attachments: 1. Leg Ver1, 2. DRAFT Sale Agrmt, 3. PUC Reso  No. 22-0070 041222, 4. Appraisal Feb 2021, 5. 
Appraisal Update Rpt 122021, 6. RED Approval of Appraisal Update Rpt Memo 011922, 7. Correction 
of APN Ltr 042821, 8. Executive Team Approving Manzano Way Property, 9. PLN Gen Pln Ref 
020420, 10. PUC Memo 051922, 11. Cmte Pkt 072022, 12. PUC Presentation 072022, 13. Board Pkt 
072622, 14. Leg Final
Action By Date Action Result Ver. RECEIVED FROM DEPARTMENT Clerk of the Board 5/19/2022 1 RECEIVED AND ASSIGNED President 6/7/2022 1 RECOMMENDED Budget and Finance Committee 7/20/2022 1 Pass ADOPTED Board of Supervisors 7/26/2022 1 Pass APPROVED Mayor 8/4/2022 1