logo City Hall
1 Dr. Carlton B. Goodlett 
Place 
San Francisco, CA  94102-
4689
City and County of San Francisco Legislation Details File #:  Version: 1 220738 Name: Disapproval of Mills Act Historical Property Contract 
- 714 Steiner Street
Status: Type: Resolution Passed File created: In control: 6/14/2022 Clerk of the Board On agenda: Final action: 6/22/2022 7/1/2022 Enactment date: 7/1/2022 296-22 Enactment #: Title: Resolution rescinding Resolution No. 225-22, which had approved a historical property contract  between Leah Culver Revocable Trust, the owner of 714 Steiner Street, Assessor’s Parcel Block No.  803, Lot No. 019, and the City and County of San Francisco, under Administrative Code, Chapter 71,  and disapproving said contract. Sponsors: Aaron Peskin Attachments: 1. Leg Ver1, 2. Prop Listing, 3. Peninsula Press 111621, 4. Business Insider 021220, 5. SF News 
052022, 6. Pink Painted Lady Tweet 052022, 7. DRAFT Mills Act Contract, 8. PLN CEQA Cat Ex Det, 
9. HPC Reso No. 1199 100621, 10. HPC Mills Act Exec Sum 100621, 11. ASR Valuation Report, 12. 
PLN Pre-approval Rpt 052821, 13. Exhibits A & B - Rehab & Maintenance Plan, 14. HPC Transmittal 
101821, 15. HPC Presentation 120221, 16. HPC Presentation 042122, 17. BOS Reso No. 225-22, 18. 
Presidential Memo - Special Meeting - 061622, 19. Board Pkt 062222, 20. Property Owner Ltr 
062022, 21. Leg Final, 22. COB Memo 070722
Action By Date Action Result Ver. REFERRED FOR ADOPTION WITHOUT 
COMMITTEE REFERENCE AGENDA AT 
THE NEXT BOARD MEETING
President 6/14/2022 1 ADOPTED Board of Supervisors 6/22/2022 1 Pass RETURNED UNSIGNED Mayor 7/1/2022 1 TRANSMITTED Clerk of the Board 7/7/2022 1