logo City Hall
1 Dr. Carlton B. Goodlett 
Place 
San Francisco, CA  94102-
4689
City and County of San Francisco Legislation Details File #:  Version: 1 221067 Name: Real Property Sale Agreement - State of California - 
Portions of SFPUC Parcel Nos. 57 and 65 - State 
Route 84 / Niles Canyon Safety Improvement 
Project in Alameda County - $11,970
Status: Type: Resolution Passed File created: In control: 10/25/2022 Clerk of the Board On agenda: Final action: 10/25/2022 11/17/2022 Enactment date: 11/17/2022 488-22 Enactment #: Title: Resolution 1) approving and authorizing the General Manager of the San Francisco Public Utilities  Commission (“SFPUC”) and/or the Director of Property, on behalf of the City and County of San  Francisco (“City”), to sell fee and easement interest in certain real property located along State Route  84 in the City of Fremont and in unincorporated Alameda County to the State of California, acting  through its California Department of Transportation (“Caltrans”); 2) approving and authorizing an  Agreement for Sale of Real Estate, Temporary Construction Easement, and Utility Easement (“Sale  Agreement”) for the sale of the Property, as defined herein, to Caltrans; 3) authorizing the SFPUC  General Manager and/or City’s Director of Property to execute the Sale Agreement, make certain  modifications, and take certain actions in furtherance of this Resolution and the Sale Agreement, as  defined herein; 4) adopting findings declaring that the real property is “surplus land” and “exempt  surplus land” pursuant to the California Surplus Land Act; 5) determining that a competitive bidding  process for the conveyance of the Property is impractical and not in the public interest, in accordance  with Administrative Code, Section 23.3; 6) adopting responsible agency findings under the California  Environmental Quality Act (“CEQA”) and Section 15091 of the CEQA Guidelines; and 7) adopting the  Planning Department’s findings that the Sale Agreement, and the transaction contemplated therein, is  consistent with the General Plan, and the eight priority policies of Planning Code, Section 101.1. Sponsors: Attachments: 1. Leg Ver1, 2. DRAFT Executed Sales Agmt 052722, 3. PUC Declaration of Underutilization Memo 
051821, 4. Project Overview Map 100815, 5. PSA Exhibit B 052421, 6. Niles Canyon Safety 
Improvement RAF 072722, 7. Appendix D MMMRPs 103017, 8. RED Env Commitments Record 
103017, 9. CEQA Findings 011818, 10. Final EIR-RA with FONSI 011818, 11. GPR 042921, 12. NEPA 
CEQA Revalidation Form 063022, 13. PUC Reso No. 22-0159 091322, 14. PUC Memo 060221, 15. 
PUC Cover Ltr 100722, 16. Cmte Pkt 110922, 17. PUC Presentation 110922, 18. Board Pkt 111522, 
19. Leg Final
Action By Date Action Result Ver. RECEIVED FROM DEPARTMENT Clerk of the Board 10/7/2022 1 RECEIVED AND ASSIGNED President 10/25/2022 1 RECOMMENDED Budget and Finance Committee 11/9/2022 1 Pass ADOPTED Board of Supervisors 11/15/2022 1 Pass APPROVED Mayor 11/17/2022 1