logo City Hall
1 Dr. Carlton B. Goodlett 
Place 
San Francisco, CA  94102-
4689
City and County of San Francisco Legislation Details File #:  Version: 2 221156 Name: Lease and Property Management Agreement - 
Dolores Street Community Services - 5630-5638 
Mission Street - Not to Exceed $10,741,000; Certain 
Administrative Code Waivers
Status: Type: Ordinance Passed File created: In control: 11/15/2022 Clerk of the Board On agenda: Final action: 1/11/2023 Enactment date: 1/11/2023 001-23 Enactment #: Title: Ordinance 1) approving and authorizing the Director of Property and the Executive Director of the  Department of Homelessness and Supportive Housing (“HSH”) to enter into a Lease and Property  Management Agreement (“Agreement”) with Dolores Street Community Services to lease, operate,  and maintain the real property and residential improvements at 5630-5638 Mission Street (“Property”)  for an initial five-year term to commence upon the first day of the month following the effective date of  this Ordinance with one five-year option to extend, and base rent of $1 per year with no annual rent  increases, and for net property management and operating costs to be paid by the City in a total five- year amount not to exceed $10,741,000; 2) determining, in accordance with Administrative Code,  Section 23.33, that the below market rent payable under the Agreement will serve a public purpose by  providing Permanent Supportive Housing for formerly homeless and low-income households; 3)  adopting findings that the Property is “exempt surplus land” under the California Surplus Land Act; 4)  exempting the Property from contracting requirements in Administrative Code, Chapter 6, but  requiring compliance with the prevailing wage and apprenticeship requirements of Administrative  Code, Section 23.61; 5) authorizing the Director of Property and the Executive Director of HSH to  make certain modifications to the Agreement and take certain actions in furtherance of the Agreement  and this Ordinance, as defined herein; 6) ratifying all prior actions taken by any City employee or  official with respect to the Agreement; and 7) affirming the Planning Department’s determination under  the California Environmental Quality Act, and adopting the Planning Department’s findings that the  Agreement is consistent with the General Plan, and the eight priority policies of Planning Code,  Section 101.1. Sponsors: Mayor, Ahsha Safai Attachments: 1. Leg Ver1, 2. Leg Dig Ver1, 3. DRAFT Lease & Property Mgmnt Agrmt, 4. PLN Ntc Proj Eligible 
AB2162 Approval 111422, 5. PLN Gen Pln Ref 111422, 6. Solicitation of Info #134.1 102921, 7. CSC 
Approval 081522, 8. RED Ltr 111022, 9. Form 126, 10. Presidential Action Memo - 30 Day Waiver 
111722, 11. BLA Rpt 12/0722, 12. Cmte Pkt 120722, 13. HSH Presentation 120722, 14. Leg Ver2, 15. 
Leg Dig Ver2, 16. Board Pkt 121322, 17. Board Pkt 011023, 18. Leg Final, 19. Form 126 Final, 20. 
Executed Lease and Property Management Agreement 030123
Action By Date Action Result Ver. ASSIGNED President 11/15/2022 1 AMENDED, AN AMENDMENT OF THE 
WHOLE BEARING NEW TITLE
Budget and Finance Committee 12/7/2022 1 Pass RECOMMENDED AS AMENDED Budget and Finance Committee 12/7/2022 2 Pass PASSED ON FIRST READING Board of Supervisors 12/13/2022 2 Pass FINALLY PASSED Board of Supervisors 1/10/2023 2 Pass APPROVED Mayor 1/11/2023 2 RECEIVED FROM DEPARTMENT Clerk of the Board 3/9/2023 2