logo City Hall
1 Dr. Carlton B. Goodlett 
Place 
San Francisco, CA  94102-
4689
City and County of San Francisco Legislation Details File #:  Version: 1 241120 Name: Authorizing Refunding Certificates of Participation - 
Various Port Projects - Not to Exceed $25,000,000
Status: Type: Ordinance Passed File created: In control: 11/19/2024 Clerk of the Board On agenda: Final action: 2/14/2025 Enactment date: 2/14/2025 014-25 Enactment #: Title: Ordinance authorizing the execution and delivery from time to time of refunding Certificates of  Participation evidencing and representing an aggregate principal amount of not to exceed  $25,000,000 to prepay certain certificates of participation that financed the design, acquisition,  construction, reconstruction, expansion, improvement, equipping, renewal, restoration, and/or  replacement of certain capital improvements to properties of the Port Commission of the City and  County of San Francisco; approving the form of Supplement to Trust Agreement between the City and  County of San Francisco and U.S. Bank Trust Company, National Association (as successor-in- interest to U.S. Bank National Association), as trustee (“Trustee”); approving the form of Supplement  to Project Lease, between the City and County of San Francisco and the Trustee, relating to the lease  and lease back of all or a portion of the James R. Herman Cruise Terminal at Pier 27; approving the  form of Escrow Agreement, Purchase Contract, Official Notice of Sale, and Notice of Intention to Sell  Certificates; directing the publication of the Notice of Intention to Sell Certificates; approving the form  of the Preliminary Official Statement and the form and execution of the Official Statement relating to  the sale of the Certificates; approving the form of the Continuing Disclosure Certificate; granting  general authority to City officials to take necessary actions in connection with the authorization,  execution, sale and delivery of the Certificates, approving modifications to documents and  agreements; and ratifying previous actions taken in connection therewith, as defined herein. Sponsors: Mayor Attachments: 1. Leg Ver1, 2. Leg Dig Ver1, 3. DRAFT 1st Supplement - Trust Agrmt, 4. DRAFT 2nd Supplement to 
Project Lease, 5. DRAFT Escrow Agreement, 6. DRAFT Purchase Contract, 7. DRAFT Notice of 
Intent to Sell, 8. DRAFT Official Notice of Sale, 9. DRAFT Preliminary Official Statement, 10. CON 
Memo 111924, 11. OPF Presentation 012925, 12. BLA Rpt 012925, 13. Cmte Pkt 012925, 14. Board 
Pkt 020425, 15. Board Pkt 021125, 16. Leg Final
Action By Date Action Result Ver. ASSIGNED UNDER 30 DAY RULE President 11/19/2024 1 RECOMMENDED Budget and Finance Committee 1/29/2025 1 Pass PASSED ON FIRST READING Board of Supervisors 2/4/2025 1 Pass FINALLY PASSED Board of Supervisors 2/11/2025 1 Pass APPROVED Mayor 2/14/2025 1